Loading...
03 27 23 City Council MinutesNew Hope City Council  March 27, 2023  Page 1   City of New Hope  4401 Xylon Avenue North  New Hope, Minnesota 55428    City Council Minutes March 27, 2023  Regular Meeting City Hall, 7:00 p.m.      CALL TO ORDER The New Hope City Council met in regular session pursuant to due call and notice  thereof; Mayor Hemken called the meeting to order at 7:00 p.m.    PLEDGE OF  ALLEGIANCE    The City Council and all present stood for the Pledge of Allegiance.  ROLL CALL Council present:          Absent:    Staff present:       Kathi Hemken, Mayor  John Elder, Council Member  Andy Hoffe, Council Member  Michael Isenberg, Council Member    Jonathan London, Council Member    Tim Hoyt, Acting City Manager  Valerie Leone, City Clerk  Susan Rader, Director of Parks & Recreation  Jeff Sargent, Director of Community Development  Stacy Woods, City Attorney    APPROVAL OF  MINUTES  Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member Hoffe,  to approve the regular meeting minutes of March 13, 2023. Voted in favor thereof:  Hemken, Elder, Hoffe, Isenberg; and the following voted against the same: None;  Abstained: None; Absent: London. Motion carried.    OPEN FORUM    There was no one present desirous of addressing the council.  ROTATING VOTES    Please note that votes taken on each agenda item are called by the secretary on a  rotating basis; however, the written minutes always list the mayor’s name first  followed by the council members’ in alphabetical order.    CONSENT AGENDA Mayor Hemken introduced the consent items as listed for consideration and stated  that all items will be enacted by one motion unless requested that an item be  removed for discussion. Mr. Tim Hoyt, acting city manager, reviewed the consent  items.    FINANCIAL CLAIMS  Item 6.2    Approval of financial claims through March 27, 2023.  MOTION  Item 6.4    Motion approving amendments to the Human Rights Commission Mission  Statement and Bylaws.      New Hope City Council  March 27, 2023  Page 2   MOTION  Item 6.5    Motion to accept a $1,500 donation in memory of Bruce and Shirley Berglin.     Ms. Susan Rader, director of parks and recreation, explained the generous  donation for a memorial bench was made by Wendy Becker, Lisa Fay, and Terry  Berglin in honor of their parents.    Council Member Elder thanked the family members on behalf of the city.    MOTION  Item 6.6    Motion waiving permit fees for temporary signs for New Hope Lions Pancake  Breakfast on April 16, 2023.  RESOLUTION 2023‐38  Item 6.7    Resolution approving final payment to Sunram Construction, Inc. in the amount  of $156,065.16 for the construction of the city hall and pool parking lots, land‐ scaping, and park trails (Improvement Project Nos. 994/941).    MOTION  Consent Items  Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member  Isenberg, to approve the Consent items. All present voted in favor. Motion  carried.    RENTAL LICENSE  REVOCATION   3959 OREGON AVE N  Item 10.1    Mayor Hemken introduced for discussion Item 10.1, Resolution establishing  findings of fact and conclusions of law relating to revocation of rental property  registration permit for Richard Swenson for having a third instance of disorderly  behavior at the property located at 3959 Oregon Avenue North.    Mr. Jeff Sargent, director of community development, explained a public hearing  to consider the revocation of the rental property registration permit for 3959  Oregon Avenue North was held at the March 13, 2023, City Council Meeting.  Disorderly behavior slips were issued to residents at the property on September 2,  2022, January 13, 2023, and January 16, 2023. At the March 13, 2023, City Council  meeting, the City Council heard relevant evidence and arguments and reviewed  all testimony, documents, and other evidence submitted related to issuance of the  disorderly behavior slips. It was determined that the property owner had violated  Section 3‐31(i) of the City Code by allowing tenants of the property to engage in  three or more acts of disorderly behavior at the property within a 12‐month period.    He stated following the public hearing at the March 13, 2023, City Council Meeting,  staff was directed to prepare a resolution revoking the rental registration permit  for Richard Swenson, as the owner of the property of 3959 Oregon Avenue North  and prohibiting the owner from re‐applying for another rental registration permit  for 3959 Oregon Avenue North or any other property in the city of New Hope for  a period of three years. The resolution requires that tenants of 3959 Oregon Avenue  North must vacate the property within 60 days (May 26, 2023) and prohibits the  property owner from having an ownership interest in any other entity that  attempts to apply for another rental registration permit for 3959 Oregon Avenue  North or any other property in the city for three years.    Staff recommends that the City Council consider a resolution establishing findings  of fact and conclusions of law relating to the revocation of a rental property  registration permit for Richard Swenson for violations of rental property  New Hope City Council  March 27, 2023  Page 3   registration permit requirements for having a third instance of disorderly behavior  at the property located at 3959 Oregon Avenue North.    Council Member Elder reported it is necessary for the Council to take action to  protect the community. He expressed support for adoption of the resolution.  He  also thanked the property owner for attending the March 13 Council Meeting and  explaining the situation.     RESOLUTION 2023‐39  Item 10.1  Council Member Elder introduced the following resolution and moved its  adoption: “RESOLUTION ESTABLISHING FINDINGS OF FACT AND  CONCLUSIONS OF LAW RELATING TO REVOCATION OF RENTAL  PROPERTY REGISTRATION PERMIT FOR RICHARD SWENSON FOR  HAVING A THIRD INSTANCE OF DISORDERLY BEHAVIOR AT THE  PROPERTY LOCATED AT 3959 OREGON AVENUE NORTH.” The motion for  the adoption of the foregoing resolution was seconded by Council Member Hoffe,  and upon vote being taken thereon, the following voted in favor thereof: Hemken,  Elder, Hoffe, Isenberg; and the following voted against the same: None; Abstained:  None; Absent: London; whereupon the resolution was declared duly passed and  adopted, signed by the mayor which was attested to by the city clerk.    EXCHANGE OF   COMMUNICATION  Item 12.1  Mayor Hemken introduced for discussion Item 12.1, Exchange of communication  between members of the City Council.    Mayor Hemken reported on upcoming events.    ADJOURNMENT    Motion was made by Council Member Isenberg, seconded by Council Member  Elder, to adjourn the meeting, as there was no further business to come before  the Council. All present voted in favor. Motion carried. The New Hope City  Council adjourned at 7:11 p.m.  Respectfully submitted,    Valerie Leone, City Clerk