Loading...
10 26 20 City Council MinutesNew Hope City Council  October 26, 2020  Page 1   City of New Hope  4401 Xylon Avenue North  New Hope, Minnesota 55428    City Council Minutes October 26, 2020  Regular Meeting City Hall, 7:00 p.m.      CALL TO ORDER The New Hope City Council met in regular session pursuant to due call and notice  thereof; Mayor Hemken called the meeting to order at 7:00 p.m.    PLEDGE OF  ALLEGIANCE    The City Council and all present stood for the Pledge of Allegiance.  ROLL CALL Council present:            Staff present:       Kathi Hemken, Mayor  John Elder, Council Member  Cedrick Frazier, Council Member  Andy Hoffe, Council Member  Jonathan London, Council Member    Kirk McDonald, City Manager  Dan Boyum, City Engineer  Rich Johnson, Director of HR/Admin. Services  Valerie Leone, City Clerk  Bernie Weber, Director of Public Works  Stacy Woods, Assistant City Attorney    APPROVAL OF  MINUTES  Motion was made by Council Member Hoffe, seconded by Council Member  Frazier, to approve the regular meeting minutes of September 28, 2020. Voted in  favor thereof: Hemken, Elder, Frazier, Hoffe; and the following voted against the  same: None; Abstained: London; Absent: None. Motion carried.    Motion was made by Council Member Frazier, seconded by Council Member  Hoffe, to approve the regular meeting minutes of October 12, 2020. Voted in favor  thereof: Hemken, Elder, Frazier, Hoffe, London; and the following voted against  the same: None; Abstained: None; Absent: None. Motion carried.    OPEN FORUM    There was no one present desirous of addressing the council.  ROTATING VOTES    Please note that votes taken on each agenda item are called by the secretary on a  rotating basis; however, the written minutes always list the mayor’s name first  followed by the council members’ in alphabetical order.    CONSENT AGENDA Mayor Hemken introduced the consent items as listed for consideration and stated  that all items will be enacted by one motion unless requested that an item be  removed for discussion. Mr. Kirk McDonald, city manager, reviewed the consent  items.    FINANCIAL CLAIMS  Item 6.2  Approval of financial claims through October 26, 2020.  New Hope City Council  October 26, 2020  Page 2     RSOLUTION 2020‐100  Item 6.4    Resolution electing to participate in the Local Housing Incentives Account  Program under the Metropolitan Livable Communities Act.  RESOLUTION 2020‐101  Item 6.5    Resolution approving assessment services agreement with Hennepin County for  years 2021‐2024.  RESOLUTION 2020‐102  Item 6.6    Resolution approving 2021 maintenance agreement with Embedded Systems, Inc.  for tornado/civil defense siren maintenance in the amount of $1,660.32.    RESOLUTION 2020‐103  Item 6.7  Resolution approving final payment to American Liberty Construction, Inc. in the  amount of $5,000.00 for the construction of the outdoor theater and picnic shelter  at Civic Center Park (Improvement Project No. 941).    MOTION  Consent Items  Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member Hoffe,  to approve the Consent items. All present voted in favor. Motion carried.    2021  INFRASTRUCTURE  PROJECT  (IMPROVEMENT  PROJECT NO. 1054)  Item 7.1    Mayor Hemken introduced for discussion Item 7.1, Resolution ordering the  construction of and preparation of plans and specifications for the 2021  Infrastructure Project (Improvement Project No. 1054).    Mr. Dan Boyum, city engineer, reviewed the project area and project components.  The project consists of street and utility improvements in the Lions Park  neighborhood and Erickson Drive. The estimated project cost is $1,706,932.89 (base  bid) and could increase to $2,000,082.89 if one of the two storm alternates  associated with the sliplining or open‐cut replacement of the storm sewer line on  Oregon Avenue is awarded. He stated the majority of the project will be funded  by the city’s street infrastructure and enterprise funds. There are two tax‐exempt  properties (Lions Park and The Salvation Army) that will also contribute as a  funding source through special assessments.     Mr. Boyum responded to questions from Council regarding the former use of  petromat for street projects, average street life, and improvements to reduce I&I  (inflow and infiltration).    There was no one present in the audience desirous of addressing the Council for  the public hearing.    CLOSE HEARING   Item 7.1  Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member  Frazier, to close the public hearing. All present voted in favor. Motion carried.    RESOLUTION 2020‐104  Item 7.1  Council Member London introduced the following resolution and moved its  adoption: “RESOLUTION ORDERING THE CONSTRUCTION OF AND  PREPARATION OF PLANS AND SPECIFICATIONS FOR THE 2021  INFRASTRUCTURE PROJECT (IMPROVEMENT PROJECT NO. 1054).” The  motion for the adoption of the foregoing resolution was seconded by Council  Member Frazier, and upon vote being taken thereon, the following voted in favor  thereof: Hemken, Elder, Frazier, Hoffe, London; and the following voted against  the same: None; Abstained: None; Absent: None; whereupon the resolution was  New Hope City Council  October 26, 2020  Page 3   declared duly passed and adopted, signed by the mayor which was attested to by  the city clerk.    2020 CITY  CONTRIBUTION FOR  HEALTH BENEFITS  Item 10.1  Mayor Hemken introduced for discussion Item 10.1, Resolution establishing city’s  monthly contribution for health benefits programs effective January 1, 2021.    Mr. Rich Johnson, director of HR/administrative services, requested approval of an  increase to the city’s contribution for health benefits programs for city employees  effective January 1, 2021. He explained the Council reviewed the item at its October  19 work session. He stated the city’s open enrollment begins soon.     RESOLUTION 2020‐105  Item 10.1  Council Member Elder introduced the following resolution and moved its  adoption: “RESOLUTION ESTABLISHING CITY’S MONTHLY  CONTRIBUTION FOR HEALTH BENEFITS PROGRAMS EFFECTIVE  JANUARY 1, 2021.” The motion for the adoption of the foregoing resolution was  seconded by Council Member London, and upon vote being taken thereon, the  following voted in favor thereof: Hemken, Elder, Frazier, Hoffe, London; and the  following voted against the same: None; Abstained: None; Absent: None;  whereupon the resolution was declared duly passed and adopted, signed by the  mayor which was attested to by the city clerk.    PURCHASE OF  EQUIPMENT   Item 10.2  Mayor Hemken introduced for discussion Item 10.1, Resolution authorizing the  purchase of equipment and appropriation of funds in the amount of $274,956.96 for  the purchase of a 2021 Mack‐Granite 64BR cab, chassis, dump box, asphalt patch  trailer and ancillary equipment to replace the city’s asphalt patch truck and the  purchase of two 2021 Mack‐Granite 64BR cab, chassis, dump box and ancillary  equipment to replace two plow trucks in the amount of $464,415.72, totaling  $739,372.68.    Mr. Bernie Weber, director of public works, requested approval for the purchase of  a 2021 Mack‐Granite 64BR cab, chassis, dump box and asphalt patch trailer for  $275,003.64 to replace the city’s asphalt patch truck. He stated staff also requests  approval of the purchase of two 2021 Mack‐Granite 64BR cab, chassis, dump box and  ancillary equipment to replace two plow trucks in the amount of $464,349.32, for a total  purchase of $739,352.96. One truck is included in the 2020 CIP and two trucks are  included in the 2021 CIP. The vehicle replacement fund has $782,105 dedicated for these  purchases so the purchase is $42,753 under the CIP amount. Staff recommends sending  to auction three dump trucks (1999 Sterling, 2000 Sterling, and 2010 International  models). The advantages of ordering the trucks now include cost savings by getting  2020 vehicle rates, not having to pay until 2021, and the ability to use the equipment for  snow plowing in early 2021.    Mr. Kirk McDonald, city manager, stated the purchase is $42,000 less than the amount  included in the CIP.     RESOLUTION 2020‐106  Item 10.2  Council Member Elder introduced the following resolution and moved its  adoption: “RESOLUTION AUTHORIZING THE PURCHASE OF EQUIPMENT  AND APPROPRIATION OF FUNDS IN THE AMOUNT OF $274,956.96 FOR  THE PURCHASE OF A 2021 MACK‐GRANITE 64BR CAB, CHASSIS, DUMP  BOX, ASPHALT PATCH TRAILER AND ANCILLARY EQUIPMENT TO  New Hope City Council  October 26, 2020  Page 4   REPLACE THE CITY’S ASPHALT PATCH TRUCK AND THE PURCHASE OF  TWO 2021 MACK‐GRANITE 64BR CAB, CHASSIS, DUMP BOX AND  ANCILLARY EQUIPMENT TO REPLACE TWO PLOW TRUCKS IN THE  AMOUNT OF $464,415.72, TOTALING $739,372.68.” The motion for the adoption  of the foregoing resolution was seconded by Council Member Frazier, and upon  vote being taken thereon, the following voted in favor thereof: Hemken, Elder,  Frazier, Hoffe, London; and the following voted against the same: None;  Abstained: None; Absent: None; whereupon the resolution was declared duly  passed and adopted, signed by the mayor which was attested to by the city clerk.    EXCHANGE OF   COMMUNICATION  Item 12.1  Mayor Hemken introduced for discussion Item 12.1, Exchange of communication  between members of the City Council.    Mayor Hemken reported on upcoming events.    Council Member Frazier reported that Council interviewed commission  candidates prior to the Council Meeting. Council unanimously appointed Mindy  London and Danielle Saima to the Human Rights Commission for two‐year terms.     ADJOURNMENT    Motion was made by Council Member Frazier, seconded by Council Member  Elder, to adjourn the meeting, as there was no further business to come before  the Council. All present voted in favor. Motion carried. The New Hope City  Council adjourned at 7:36 p.m.  Respectfully submitted,    Valerie Leone, City Clerk