Loading...
04 13 20 City Council MinutesNew Hope City Council  April 13, 2020  Page 1   City of New Hope  4401 Xylon Avenue North  New Hope, Minnesota 55428    City Council Minutes April 13, 2020  Regular Meeting City Hall, 7:00 p.m.      CALL TO ORDER The New Hope City Council met in regular session pursuant to due call and notice  thereof; Mayor Hemken called the meeting to order at 7:00 p.m.      Due to the COVID‐19 pandemic, some members of the Council, city staff, and  consultants participated remotely.      PLEDGE OF  ALLEGIANCE    Mayor Hemken announced that the Pledge would not be recited since the meeting  is not being held in the council chambers.    ROLL CALL Council present:            Staff present:       Kathi Hemken, Mayor  John Elder, Council Member  Cedrick Frazier, Council Member  Andy Hoffe, Council Member  Jonathan London, Council Member    Kirk McDonald, City Manager  Rich Johnson, Director of HR/Admin. Services  Valerie Leone, City Clerk  Stacy Woods, Assistant City Attorney    APPROVAL OF  MINUTES  Motion was made by Council Member Hoffe, seconded by Council Member Elder,  to approve the work session minutes of March 16, 2020. Voted in favor thereof:  Hemken, Elder, Frazier, Hoffe, London; and the following voted against the same:  None; Abstained: None; Absent: None. Motion carried.    Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member Hoffe,  to approve the regular meeting minutes of March 23, 2020. Voted in favor thereof:  Hemken, Elder, Frazier, Hoffe, London; and the following voted against the same:  None; Abstained: None; Absent: None. Motion carried.    OPEN FORUM    There was no one present desirous of addressing the council.  ROTATING VOTES    Please note that votes taken on each agenda item are called by the secretary on a  rotating basis; however, the written minutes always list the mayor’s name first  followed by the council members’ in alphabetical order.    CONSENT AGENDA Mayor Hemken introduced the consent items as listed for consideration and stated  that all items will be enacted by one motion unless requested that an item be  removed for discussion. Mr. Kirk McDonald, city manager, reviewed the consent  items.    New Hope City Council  April 13, 2020  Page 2   FINANCIAL CLAIMS  Item 6.2    Approval of financial claims through April 13, 2020.  RESOLUTION 2020‐43  Item 6.4    Resolution proclaiming the month of May 2020, as Arbor Month in the city of  New Hope.  RESOLUTION 2020‐44  Item 6.5    Resolution proclaiming May 17‐23, 2020, as National Public Works Week in the  city of New Hope.  RESOLUTION 2020‐45  Item 6.6    Resolution proclaiming April 19‐25, 2020 as National Crime Victims’ Rights  Week in the city of New Hope.  RESOLUTION 2020‐46  Item 6.7  Resolution approving renewing the agreement with Solution Builders to provide  information technology support services for the city effective May 1, 2020 to  April 30, 2021.    MOTION  Consent Items  Motion was made by Council Member London, seconded by Council Member  Frazier, to approve the Consent items. All present voted in favor. Motion carried.    RENEWAL OF  INSURANCE  PREMIUMS  Item 11.1  Mayor Hemken introduced for discussion Item 11.1, Motion approving renewal of  insurance premiums for general liability, property damage, employee bond and  worker’s compensation for the period April 20, 2020 through April 20, 2021  through the League of Minnesota Cities Insurance Trust (LMCIT).    Mr. Kirk McDonald, city manager, explained the city clerk coordinates renewal of  the general liability insurance and the director of human resources and  administrative services handles the workers’ compensation insurance renewal.  Mr. McDonald stated the premium for the property/liability coverage increased  from $160,114 to $189,767 or $29,653 from last year (primarily due to the new city  hall/police department).     Mr. McDonald stated the workers’ compensation premium increased from  $226,558 to $232,755 or $6,197 from last year. He stated staff is recommending the  city continue with a $5,000 deductible for workers’ compensation insurance. He  stated the payroll basis included the addition of pool operations and the cost of  living adjustments. He explained years 2016, 2017, and 2018 are used to establish  the city’s experience modification rate. He stated the rate decreased from 1.05 to  .92 for workers’ compensation insurance.     Mr. McDonald stated the total insurance expense is $422,522 which is below the  2020 budgeted amount of $449,888.    MOTION  Item 11.1  Motion was made by Council Member Elder, seconded by Council Member  Frazier, approving renewal of insurance premiums for general liability, property  damage, employee bond and worker’s compensation for the period April 20,  2020 through April 20, 2021 through the League of Minnesota Cities Insurance  Trust (LMCIT). All present voted in favor. Motion carried.    New Hope City Council  April 13, 2020  Page 3   LMCIT STATUTORY  LIMITATIONS  Item 11.2  Mayor Hemken introduced for discussion Item 11.2, Motion to accept statutory  limitations of $500,000 for individual claimant recovery for insurance provided by  League of Minnesota Cities Insurance Trust (LMCIT).    Mr. Kirk McDonald, city manager, recommended the Council take action similar  to prior years to accept the statutory limitation for individual claimant recovery.  He stated that if the city waived the statutory tort limits, a single claimant could  potentially recover up to $2,000,000 per occurrence compared to $500,000.     MOTION  Item 11.2  Motion was made by Council Member London, seconded by Council Member  Elder, to accept statutory limitations of $500,000 for individual claimant recovery  for insurance provided by League of Minnesota Cities Insurance Trust (LMCIT).  All present voted in favor. Motion carried.    EXCHANGE OF   COMMUNICATION  Item 12.1  Mayor Hemken introduced for discussion Item 12.1, Exchange of communication  between members of the City Council.    Mayor Hemken reported on upcoming events.    ADJOURNMENT    Motion was made by Council Member Frazier, seconded by Council Member  Elder, to adjourn the meeting, as there was no further business to come before  the Council. All present voted in favor. Motion carried. The New Hope City  Council adjourned at 7:12 p.m.  Respectfully submitted,    Valerie Leone, City Clerk